SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2024-82-28)
MADRID
49 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 82

Viernes 26 de abril de 2024

Pág. 21365

(19.04.24).
201299 - MEDILLOCAL Y COMPAÑIA SA.
Nombramientos. Apoderado: TOLEDO CARPIO KATTY-ALEXANDRA. Datos registrales. T 30607 , F 194, S 8, H M 94635, I/A 22
(19.04.24).
201300 - MOUNTPARK PROPERTIES SL.
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 141 21 - MODULO A (MADRID). Datos registrales. T 35343 , F 4, S 8,
H M 635370, I/A 6 (19.04.24).
201301 - FUERZAS ENERGETICAS DEL SUR DE EUROPA XXV SL.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: NEARCO RENOVABLES SL. Datos registrales. T 35987 , F 176, S 8, H M 646608,
I/A 6 (19.04.24).
201302 - ECONOMIC VALUE GAMBLING SL.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: CALIOPE INNOVA SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AUDITORY BUSINESS
ACCOUNT SL. Representan: JIMENEZ DE-LA-CRUZ JOSE-ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: CALIOPE INNOVA SL.
Representan: PEREZ AGUEDA ROBERTO. Datos registrales. T 40749 , F 50, S 8, H M 722957, I/A 5 (19.04.24).
201303 - FUERZAS ENERGETICAS DEL SUR DE EUROPA XXVI SL.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: NEARCO RENOVABLES SL. Datos registrales. T 35987 , F 185, S 8, H M 646609,
I/A 6 (19.04.24).
201304 - FUERZAS ENERGETICAS DEL SUR DE EUROPA XXVII SL.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: NEARCO RENOVABLES SL. Datos registrales. T 35998 , F 7, S 8, H M 646802,
I/A 6 (19.04.24).
201305 - NUVA URBAN ASSETS, S.L.
Nombramientos. Apoderado: MORAN BAENA JAIME. Datos registrales. T 42874 , F 215, S 8, H M 758019, I/A 7 (19.04.24).
201306 - CREACIONES MIRTO SA.
Revocaciones. Apoderado: MENDEZ GUZMAN MANUEL. Datos registrales. T 38185 , F 222, S 8, H M 82896, I/A 81 (19.04.24).
201307 - JARA CINCUENTA SL.
Ampliación de capital. Capital: 70.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 73.010,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de
los estatutos: 5. Datos registrales. T 14189 , F 94, S 8, H M 233467, I/A 11 (19.04.24).
201308 - AHUMADOS DOMINGUEZ SA.
Otros conceptos: SE SUBSANA EL ERROR MATERIAL COMETIDO EN CUANTO AL SEGUNDO APELLIDO DE LA APODERADA
NOMBRADA EN LA QUE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 58ª, SIENDO EL NOMBRE COMPLETO CORRECTO: DOÑA
MONICA FERNANDEZ CHAICHIO. Datos registrales. T 42590 , F 64, S 8, H M 117763, I/A 59 (19.04.24).
201309 - REDECOR CR SL.
Ampliacion del objeto social. - Comercio al por menor de todo tipo de vehículos terrestres.- Comercio al por menor de accesorios y
piezas de recambio para vehículos terrestres. Datos registrales. T 45645 , F 146, S 8, H M 802625, I/A 2 (19.04.24).

201311 - PERFECTA INDUSTRIAL FINANCE SL.
Nombramientos. Apoderado: D'OREY BOTELHO SIMOES ROQUE BERNARDO;SAEZ GOMEZ DE LA TORRE BORJA;QUINTEIRO
FERNANDEZ SARA. Datos registrales. T 44588 , F 94, S 8, H M 785410, I/A 4 (19.04.24).
201312 - SIGMA REPARACIONES SL.
Ceses/Dimisiones. Representan: BARTOLOME DELICADO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: OBLIGI ALEXIS
PATRICK OLIVER. Datos registrales. T 46106 , F 186, S 8, H M 311568, I/A 65 (19.04.24).
201313 - SIGMA REPARACIONES SL.
Revocaciones. Apoderado: MOLLEDA FERNANDEZ JOSE-ANTONIO. Apo.Manc.: BARTOLOME DELICADO FRANCISCO JAVIER.
Apoderado: MOLLEDA FERNANDEZ JOSE-ANTONIO;ASTARLOA ECHEVARRIETA IÑIGO;MOLLEDA FERNANDEZ JOSE
ANTONIO. Apo.Man.Soli: SEGURA ROMERO ANA. Apo.Manc.: BARTOLOME DELICADO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales.
T 46106 , F 186, S 8, H M 311568, I/A 66 (19.04.24).

cve: BORME-A-2024-82-28
Verificable en https://www.boe.es

201310 - ARESBANK SOCIEDAD ANONIMA.
Revocaciones. Apoderado: FERDI ROUBAI AMEL;FERDI ROUBAI AMEL. Datos registrales. T 11230 , F 154, S 8, H M 111123, I/A
376 (19.04.24).