SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2024-60-28)
MADRID
54 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 60

Lunes 25 de marzo de 2024

Pág. 15686

149010 - SANCHEZ DEL CAÑO SL.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: SANCHEZ DEL CAÑO SERGIO. Reducción de capital. Importe reducción:
101.667,19 Euros. Resultante Suscrito: 59.704,53 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Reducido el
Capital social.-. Artículo de los estatutos: 2. Cambiado el domicilio social. Artículo de los estatutos: 3. Cambiado el Objeto social.-.
Cambio de domicilio social. C/ REPUBLICA DOMINICANA 3 (VILLANUEVA DE LA CAÑADA). Cambio de objeto social. La
Sociedad tendrá por objeto: a) La compra, venta, diseño, confección, fabricación, comercialización al por mayor y al detalle, la
exportación e importación de prendas de vestido y de tocado para todo tipo de personas. b) La compra, venta, alquiler, construcción y
promoción de toda clase de inmue. Datos registrales. T 11392 , F 196, S 8, H M 178954, I/A 11 (18.03.24).
149011 - PEYAN2 CONSULTORES SL.
Cambio de domicilio social. C/ COSTANILLA DEL OLIVAR 1 - 2ª PLANTA OFICINA 5 (POZUELO DE ALARCON). Datos
registrales. T 27621 , F 182, S 8, H M 497745, I/A 6 (18.03.24).
149012 - BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA.
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 45249 , F 81, S 8, H M 7766, I/A
9635 (18.03.24).
149013 - BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA.
Nombramientos. Apoderado: LOVERA MORENO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 45249 , F 82, S 8, H M 7766, I/A 9636
(18.03.24).
149014 - PERMIRA ASESORES SL.
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34898 , F 39, S 8, H M 346073, I/A
35 (18.03.24).
149015 - PERMIRA ASESORES SL.
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BURGOS ALCAIDE CARMEN. VsecrNoConsj: BUIGUES SANTAMARIA JOSE FERNANDO.
Nombramientos. SecreNoConsj: ALBERTE LISTA ALEJANDRO. VsecrNoConsj: RODRIGUEZ PEREZ LUCIA. Datos registrales. T
34898 , F 39, S 8, H M 346073, I/A 36 (18.03.24).
149016 - PERMIRA ASESORES SL.
Revocaciones. Apoderado: PELAEZ AROSA JAIME;GARRIDO BUJAN MARTA;AYUSO ARRANZ ABEL. Nombramientos.
Apoderado: AGUILAR RODRIGUEZ PATRICIA;GUERRA LOPEZ FERNANDO;MALDONADO MAC-CROHON SANTIAGO. Datos
registrales. T 34898 , F 40, S 8, H M 346073, I/A 37 (18.03.24).
149017 - PUERTA & HARLOFF INVEST SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PUERTA BENAVENTE LUIS-ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: AVRAMOV HARLOV
HRISTO. Datos registrales. T 46052 , F 22, S 8, H M 809143, I/A 2 (18.03.24).
149018 - TERVEU SOLAR SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SAMBOAL MARTIN LUIS JAVIER. Nombramientos. Adm. Solid.: VICENTE MAZARIEGOS
ALVAREZ DE TOLEDO GONZALO;PRESA AMENGUAL MARCOS ANTONIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de
Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Datos registrales. T 45413 , F 33, S 8, H M 798815, I/A 2
(18.03.24).
149019 - REPSOL SA.
Nombramientos. Apoderado: MOYA PACHECO ESTER. Datos registrales. T 41236 , F 187, S 8, H M 65289, I/A 926 (18.03.24).

149021 - FICI SA.
Cambio de domicilio social. C/ KERRIA 32 2º B (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 40427 , F 1, S 8, H M 50569, I/A 21
(18.03.24).
149022 - SOLVENT BUSINESS SL.
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DIAZ NURIA. Datos registrales. T 33455 , F 89, S 8, H M 602175, I/A 7 (18.03.24).
149023 - GENBRIT 2017 SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GENG CORAL RAFAEL ALBERTO. Nombramientos. Liquidador: GENG CORAL RAFAEL
ALBERTO. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 35494 , F 151, S 8, H M 638000, I/A 3 (18.03.24).

cve: BORME-A-2024-60-28
Verificable en https://www.boe.es

149020 - TARGET CONNECTION SL.
Nombramientos. Apoderado: BARAGAÑO CAVERO JOSE CELSO. Datos registrales. T 42492 , F 188, S 8, H M 559057, I/A 19
(18.03.24).