SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2024-58-09)
BURGOS
6 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 58

Jueves 21 de marzo de 2024

Pág. 14994

registrales. T 769, L 560, F 15, S 8, H BU 12354, I/A 21 (15.03.24).
142149 - GRUPO ANTOLIN-INGENIERIA SA.
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTOLIN RAYBAUD MARIE-HELENA. Vicepresid.: ANTOLIN RAYBAUD MARIE-HELENA.
Cons.Del.Sol: ANTOLIN RAYBAUD MARIE-HELENA. Nombramientos. Consejero: ANTOLIN GRANET EMMA. Vicepresid.:
ANTOLIN GRANET EMMA. Datos registrales. T 794, L 585, F 164, S 8, H BU 3606, I/A 109 (15.03.24).
142150 - GRUPO ANTOLIN-INGENIERIA SA.
Nombramientos. Cons.Del.Sol: ANTOLIN GRANET EMMA. Datos registrales. T 794, L 585, F 164, S 8, H BU 3606, I/A 110
(15.03.24).
142151 - PANADERIA PISONES SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ LORENZO MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: CUBILLO HERAS LIDIA. Datos
registrales. T 720, L 511, F 102, S 8, H BU 16683, I/A 2 (15.03.24).
142152 - PEDRO DEL BARRIO SLP.
Nombramientos. Apo.Sol.: DEL BARRIO TAJADURA ANDRES;DEL BARRIO TAJADURA PEDRO. Datos registrales. T 779, L 570,
F 129, S 8, H BU 841, I/A 9 (15.03.24).
142153 - MADIC IBERIA SL.
Nombramientos. Apo.Sol.: AMO LOPEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 663, L 454, F 209, S 8, H BU 3488, I/A 25
(15.03.24).
142154 - ASCENSORES RYCAM SL.
Otros conceptos: Practicado cierre provisional por plazo de seis meses a la hoja registral de la Sociedad ASCENSORES RYCAM SL,
absorbida por la socia única "FAIN ASCENSORES SA" NIF A28303485 inscrita en el Registro Mercantil de MADRID. Datos
registrales. T 259, L 50, F 108, S 8, H BU 1703, I/A 17 N (15.03.24).
142155 - ASINTEC GESTION SL.
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA CERDA IZQUIERDO JOSE MARIA. Datos registrales. T 789, L 580, F 183, S 8, H BU 6441,
I/A 9 (15.03.24).
142156 - REPARACION Y NEUMATICOS JOSE LUIS SL.
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Aud.Supl.: REVENGA GOMEZ VICENTE. Nombramientos. Aud.Supl.: STARK
AUDIT SLP. Reelecciones. Auditor: COBO VALERI FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 779, L 570, F 142, S 8, H BU 8037,
I/A 7 (15.03.24).
142157 - DEMANDAVACUNO SL.
Ampliación de capital. Capital: 1.035.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.038.010,00 Euros. Datos registrales. T 688, L 479, F
211, S 8, H BU 15752, I/A 6 (15.03.24).
142158 - DULCINEA SOLAR 75 SL.
Cambio de domicilio social. CTRA CARDEÑA 6 (MODUBAR DE LA EMPAREDADA). Datos registrales. T 597, L 388, F 133, S 8,
H BU 12887, I/A 5 (15.03.24).

142160 - MADERAS EL ENEBRAL SL.
Nombramientos. Apoderado: ORUE DEL VALLE MIREN EUKENE. Datos registrales. T 706, L 497, F 69, S 8, H BU 8448, I/A 8
(15.03.24).
142161 - PRODUCCIONES RIO TRUEBA SL.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: SOBRADO MARTINEZ RAFAEL. Datos registrales. T 761, L 552, F 224, S 8, H BU
17870, I/A 3 (15.03.24).
142162 - PRODUCCIONES RIO TRUEBA SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: SOBRADO MARTINEZ RAFAEL;LASTRA GONZALEZ FELIPE. Nombramientos. Adm. Unico:
SOBRADO MARTINEZ RAFAEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a
Administrador único. Datos registrales. T 761, L 552, F 224, S 8, H BU 17870, I/A 4 (15.03.24).

cve: BORME-A-2024-58-09
Verificable en https://www.boe.es

142159 - ALTOTERO BURGOS SL.
Cambio de domicilio social. CTRA CARDEÑA 6 (MODUBAR DE LA EMPAREDADA). Datos registrales. T 786, L 577, F 215, S 8,
H BU 18679, I/A 2 (15.03.24).