SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2024-51-26)
LA RIOJA
Página 1 Pág. 1
2 >> Página 2 >>
6 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 51

Martes 12 de marzo de 2024

Pág. 13142

SECCIÓN PRIMERA
Empresarios
Actos inscritos
LA RIOJA

124873 - RIOJANA DE HOGARES SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: OSGA REINTEGRA SL. Nombramientos. Adm. Unico: GALILEA CID OSCAR. Ampliación de
capital. Capital: 2.989.875,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.109.875,00 Euros. Cambio de objeto social. La adquisición, posesión,
administración, valoración, explotación, arrendamiento y disposición de todo clase de bienes y derechos, incluidos todo clase de
valores, participaciones y acciones, efectos comerciales, activos financieros, bienes muebles e inmuebles, propiedades inmobiliarias en
general. Datos registrales. T 629 , F 165, S 8, H LO 10922, I/A 22 ( 4.03.24).
124874 - SERVICIOS INTEGRALES MURRIETA SL.
Ampliación de capital. Capital: 6.984.464,20 Euros. Resultante Suscrito: 6.987.474,20 Euros. Cambio de objeto social. la
integración laboral y social, asistencia y servicios sociales, para personas en situación de discapacidad, ya sea física, psíquica y/o
sensorial, con la finalidad de asegurar un empleo remunerado y digno, así como la realización de un ajuste de personal y social,
mediante la realización de un aj. Datos registrales. T 851 , F 28, S 8, H LO 8605, I/A 32 ( 4.03.24).
124875 - GERONTOPLUS SL.
Nombramientos. Apo.Sol.: HERNAIZ DEL CAMPO LEONARDO;HERNAIZ LOPEZ HECTOR;HERNAIZ LOPEZ HUGO;HERNAIZ
LOPEZ EDUARDO;HERNAIZ LOPEZ VICTOR;HERNAIZ DEL CAMPO MARIA MARCELINA;HERNAIZ DEL CAMPO MARIA
ELENA;AGUADO HERNAIZ INES;AGUADO HERNAIZ ELENA. Datos registrales. T 895 , F 161, S 8, H LO 20614, I/A 2 (28.02.24).
124876 - BODEGAS Y VIÑEDOS DE GOMEZ CRUZADO SOCIEDAD LIMITADA.
Ampliación de capital. Capital: 82.266,54 Euros. Resultante Suscrito: 3.034.780,57 Euros. Ampliación de capital. Capital:
41.133,27 Euros. Resultante Suscrito: 3.075.913,84 Euros. Datos registrales. T 811 , F 18, S 8, H LO 1501, I/A 41 ( 4.03.24).
124877 - INSTALACIONES CLIFORIOJA SOCIEDAD LIMITADA.
Constitución. Comienzo de operaciones: 31.01.24. Objeto social: La sociedad tiene por objeto la realización de instalaciones de
fontanería, de frío, calor y acondicionamiento de aire.Las actividades enumeradas podrán ser realizadas por la sociedad total o
parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de las acciones o participaciones en sociedades con. Domicilio: C/ LA SOLANA
7 Ptl.4 1º C (VILLAMEDIANA DE IREGUA). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: TERREN
EZQUERRO OSCAR. Nombramientos. Adm. Unico: TERREN EZQUERRO OSCAR. Datos registrales. T 896 , F 177, S 8, H LO
20672, I/A 1 (28.02.24).
124878 - VIENTOS DE AUTOL SL.
Nombramientos. Apo.Man.Soli: WHITE JOHN KIERAN;VELASCO GAZTAÑAGA ALVARO;GONZALEZ LOPEZ CARLOS. Datos
registrales. T 886 , F 156, S 8, H LO 20065, I/A 3 (28.02.24).

124880 - VIENTOS DE AUTOL SL.
Nombramientos. Apo.Man.Soli: WHITE JOHN KIERAN;VELASCO GAZTAÑAGA ALVARO;GONZALEZ LOPEZ CARLOS. Datos
registrales. T 886 , F 157, S 8, H LO 20065, I/A 5 (29.02.24).
124881 - VIENTOS DE AUTOL SL.
Nombramientos. Apo.Sol.: WHITE JOHN KIERAN;VELASCO GAZTAÑAGA ALVARO;GONZALEZ LOPEZ CARLOS;LOPEZ LOPEZ
CRISTOBAL;MARTOS RODRIGUEZ PEDRO JOSE. Datos registrales. T 886 , F 158, S 8, H LO 20065, I/A 6 (29.02.24).
124882 - CORK SUPPLY ESPAÑA SL.
Nombramientos. Apoderado: FONTES DA ROCHA ANDRE MANUEL. Datos registrales. T 563 , F 14, S 8, H LO 9269, I/A 11
(28.02.24).

cve: BORME-A-2024-51-26
Verificable en https://www.boe.es

124879 - VIENTOS DE AUTOL SL.
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: ORSTED ONSHORE SPAIN HOLDING SL. Datos registrales. T
886 , F 157, S 8, H LO 20065, I/A 4 (28.02.24).