SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2024-51-28)
MADRID
57 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 51

Martes 12 de marzo de 2024

Pág. 13155

125117 - RIOCASTOR SL.
Cambio de domicilio social. C/ SUERO DE QUIÑONES 34-36 1ª (MADRID). Datos registrales. T 34979 , F 20, S 8, H M 629109,
I/A 3 ( 5.03.24).
125118 - PROMOTORA DE PELUQUERIAS SL.
Reducción de capital. Importe reducción: 211.818,26 Euros. Resultante Suscrito: 89.987,73 Euros. Modificaciones estatutarias.
Renumeradas las participaciones sociales del 1 al 14.973, ambos inclusive, modificando el articulo 5º de los estatutos sociales. Otros
conceptos: Modificadas las facultades delegadas a los tres consejeros delegados, don Isidro Tabernero Arcos, don Adrigh Xavier
Dias y don Ricardo Lopez Soria. Datos registrales. T 3003 , F 81, S 8, H M 51425, I/A 8 ( 5.03.24).
125119 - ASESORIA FINANCIERA Y DE GESTION SA.
Revocaciones. Apo.Manc.: ARIZA CRIADO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 36311 , F 124, S 8, H M 45547, I/A 172 (
5.03.24).
125120 - PAPERACOA SL.
Nombramientos. Apo.Sol.: OLARAN MUGICA MARIA CLOTILDE JOAQUINA;GONZALEZ VESGA JOSE MANUEL. Datos
registrales. T 46364 , F 212, S 8, H M 814365, I/A 2 ( 5.03.24).
125121 - IDEA 9 ONCE INVERSIONES SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ LLORENTE MARIA-NIEVES. Revocaciones. Apoderado: VALERO CIFUENTES
JUAN-IGNACIO. Nombramientos. Liquidador: MARTINEZ LLORENTE MARIA-NIEVES. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos
registrales. T 29343 , F 167, S 8, H M 528191, I/A 6 ( 5.03.24).
125122 - AURIGA GREEN GAS SL.
Nombramientos. Apo.Sol.: ABELLAN ESPARCIA JUAN MANUEL;RODRIGUEZ GALLEGO ALBERTO. Datos registrales. T 46424 ,
F 125, S 8, H M 812980, I/A 9 ( 5.03.24).
125123 - TRERICE INVESTMENTS CORP SL.
Nombramientos. Apo.Sol.: MOLLEJA CONDE DANIEL;DELGADO DURAN MIGUEL;DURAN POVEDA CARLOS;DELGADO
AMADOR MIGUEL. Datos registrales. T 45061 , F 120, S 8, H M 793052, I/A 4 ( 5.03.24).
125124 - ERG SOLAR TABERNAS SL.
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MARTI JOSE;VILLOLDO RUIZ OLALLO. Apo.Sol.: VILLASANTE FERRANDO JAVIER;LOPEZ
DE CEBALLOS REYNA ALVARO;PARK SHIN SO RA;LANZAS ROTA BLANCA GUADALUPE;DEL POZO FARAH DANIEL
FRANCISCO. Datos registrales. T 43507 , F 126, S 8, H M 768306, I/A 6 ( 5.03.24).
125125 - EN CLAVE JOVEN SL.
Revocaciones. Apo.Manc.: SIMANCAS JIMENEZ JOSE MANUEL;LOPEZ RODRIGUEZ RAQUEL;TORRES GARCIA
SANTIAGO;PRIETO CALLES VICENTE;LOPEZ MARTINEZ GONZALO;PRIETO CALLES VICENTE;TORRES GARCIA
SANTIAGO;LOPEZ NARANJO ROCIO. Apo.Sol.: TAVIRA GONZALEZ JUAN JERONIMO. Apo.Manc.: TORRES GARCIA
SANTIAGO;HORRILLO MARIN ANTONIO;LOPEZ MARTINEZ GONZALO;LOPEZ NARANJO ROCIO. Apo.Sol.: TAVIRA GONZALEZ
JUAN. Apoderado: TORRES GARCIA SANTIAGO;LOPEZ MARTINEZ GONZALO;HORRILLO MARIN ANTONIO;ROBLES DELGADO
MANUEL;BONILLA MARTINEZ CARMEN;TORRES GARCIA SANTIAGO;ROBLES DELGADO MANUEL;BONILLA MARTINEZ
CARMEN;LOPEZ DEL AMO JUAN CARLOS. Apo.Manc.: BONILLA MARTINEZ CARMEN;BONILLA MARTINEZ CARMEN. Datos
registrales. T 35045 , F 89, S 8, H M 245175, I/A 38 ( 5.03.24).

125127 - RIDLANDS SPAIN SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GARRIGUES CALDERON BELEN;RODRIGUEZ DE SANTOS ANTONIO;OLIVES CANTALEJO
DAVID. Nombramientos. Adm. Unico: DE KERDANET YVES GALIOT JACQUES MARIE MIORCEC. Ampliación de capital.
Capital: 268.233,00 Euros. Resultante Suscrito: 271.233,00 Euros. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración:
Administradores solidarios a Administrador único. Cambio de domicilio social. C/ AYALA 66 - 1º, IZQUIERDA (MADRID). Datos
registrales. T 46080 , F 202, S 8, H M 809634, I/A 3 ( 5.03.24).
125128 - REDENSAN SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 7.02.24. Objeto social: La inversión inmobiliaria, la compra y venta, la administración,
gestión, cesión, disfrute, tenencia, arrendamiento, rehabilitación, explotación y administración en generaí de todo tipo de inmuebles. La
explotación y gestión, por cuenta propia o ajena, sea en arriendo, alquiler, cesión o cualquier o. Domicilio: C/ RABANAL DEL CAMINO
11 ATICO 4 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: LOPE RUIZ EDUARDO. Datos registrales. T 46544
, F 100, S 8, H M 817249, I/A 1 ( 5.03.24).

cve: BORME-A-2024-51-28
Verificable en https://www.boe.es

125126 - LOIOLA LOGISTIC PLATFORMS SL.
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL.. Cambio de denominación social.
AMENABAR SEVILLA SL. Datos registrales. T 46485 , F 8, S 8, H M 816202, I/A 4 ( 5.03.24).