SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2024-48-47)
VALLADOLID
Página 1 Pág. 1
2 >> Página 2 >>
3 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 48

Jueves 7 de marzo de 2024

Pág. 12515

SECCIÓN PRIMERA
Empresarios
Actos inscritos
VALLADOLID

119180 - SERVINET CYL SL.
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALGUERO CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 1470 , F 200, S 8, H VA
26934, I/A 13 (29.02.24).
119181 - SERVINET CYL SL.
Nombramientos. Apoderado: SALGUERO CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 1470 , F 201, S 8, H VA
26934, I/A 14 (29.02.24).
119182 - ARCHTEAM SL.
Cambio de domicilio social. C/ LAGAR DEL CIEGO 3 BAJO A (VALLADOLID). Datos registrales. T 1382 , F 47, S 8, H VA 23305,
I/A 2 (29.02.24).
119183 - SOCIEDAD PROVINCIAL DE DESARROLLO DE VALLADOLID SA.
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: OLEA NIETO JUAN CARLOS. Presidente: MIGALLON GONZALEZ ROBERTO. Miem.Com.Ej.:
MIGALLON GONZALEZ ROBERTO. Pres.Com.Ej.: MIGALLON GONZALEZ ROBERTO. Con.Delegado: MIGALLON GONZALEZ
ROBERTO. Nombramientos. SecreNoConsj: JIMENEZ LOPEZ MARIA JESUS DOLORES. Consejero: LABARGA VACA
FRANCISCO JAVIER;SANTANA ALONSO MOISES. Presidente: SANTANA ALONSO MOISES. Miem.Com.Ej.: SANTANA ALONSO
MOISES. Pres.Com.Ej.: SANTANA ALONSO MOISES. Con.Delegado: SANTANA ALONSO MOISES. Reelecciones. Vicesecret.:
HERRERO TRIGOS MARIA ROSARIO. Datos registrales. T 1638 , F 73, S 8, H VA 15958, I/A 36 (29.02.24).
119184 - HOTEL RESORT EL MONTICO SL.
Ampliación de capital. Capital: 1.094.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.716.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.
ARTICULO 5º.- CAPITAL SOCIAL. La sociedad fija su capital social en la cifra de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL EUROS -1.994.000,00 E-, dividido en mil novecientas noventa y cuatro -1.994- participaciones sociales, iguales, acumulables e
indivisibles, que no podrán estar representadas por títulos o anotaciones en cuenta ni denominarse acciones;. Fe de erratas:
Revisada la valoración del inmueble aportado en la escritura de CONSTITUCION de la Sociedad, se acuerda RECTIFICAR dicha
escritura que motivó la INSCRIPCION 1ª en la Hoja abierta a la Sociedad, modificando el capital social, las participaciones, la
suscripción y el artículo correspondiente. Como consecuencia de la rectificación de la escritura de constitución se procede a
RECTIFICAR la escritura de AMPLIACION DE CAPITAL SOCIAL, que motivó la INSCRIPCION 3ª en la Hoja abierta a la Sociedad.
Datos registrales. T 1508 , F 199, S 8, H VA 28548, I/A 5 (29.02.24).
119185 - MONTE ABAJO GANADERIAS SL.
Ampliación de capital. Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.050.000,00 Euros. Datos registrales. T 1435 , F 15, S 8, H
VA 25430, I/A 5 (29.02.24).

119187 - GUNDABAR SL.
Nombramientos. Adm. Solid.: SIGUEROS FERNANDEZ MARCOS. Ampliación de capital. Capital: 25.000,00 Euros. Resultante
Suscrito: 75.000,00 Euros. Datos registrales. T 1640 , F 150, S 8, H VA 34212, I/A 2 (29.02.24).
119188 - CENTRO DE DIAGNOSTICO RECOLETAS CASTILLA Y LEON SL.
Nombramientos. Apoderado: CUESTA MOHEDANO MARIA ROSA. Datos registrales. T 1557 , F 6, S 8, H VA 22387, I/A 22
(29.02.24).
119189 - RETORNOS SANTOS SL.
Cambio de domicilio social. CTRA FUENSALDAÑA Km 0,7 (VILLANUBLA). Datos registrales. T 643 , F 24, S 8, H VA 832, I/A 8
(29.02.24).

cve: BORME-A-2024-48-47
Verificable en https://www.boe.es

119186 - SELECCION DE TORRES SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: AMADO GALLART JOSEP;MIRO VISA MIGUEL. Nombramientos. Adm. Solid.: AMADO
GALLART JOSEP;MIRO VISA MIGUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados
a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1600 , F 138, S 8, H VA 15985, I/A 30 (29.02.24).