SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2024-28-28)
MADRID
53 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 28

Jueves 8 de febrero de 2024

Pág. 7076

67755 - INDUSTRIAS G J SA.
Reelecciones. Adm. Solid.: JIMENEZ MARTIN JULIAN;JIMENEZ MARTIN MIRIAM. Datos registrales. T 4316 , F 98, S 8, H M
71627, I/A 11 ( 1.02.24).
67756 - PREMIER ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA.
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CARMONA JORGE. Datos registrales. T 44703 , F 187, S 8, H M 477067, I/A 58 ( 1.02.24).
67757 - PRANAVA SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FERNANDEZ ABAD ANA;FERNANDEZ ARGUESO ALEJANDRO AGUSTIN. Nombramientos.
Liquidador: FERNANDEZ ARGUESO ALEJANDRO AGUSTIN. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 12186 , F
158, S 8, H M 192687, I/A 8 ( 1.02.24).
67758 - INSTALACIONES MINGORANCE SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 5.01.24. Objeto social: actividad principal CNAE 4332 Instalaciones de Carpintería: - la
realización de actividades de carpintería, exposición y venta de bricolaje. -Desarrollo de la actividad de Carpintería en general,
instalaciones de parquet y tarimas, montajes de puertas y estructuras. - reformas generales, ... Domicilio: C/ RIO JARAMA 53
(ARROYOMOLINOS). Capital: 3.006,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: MINGORANCE JIMENEZ ANTONIO
FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico: MINGORANCE JIMENEZ ANTONIO FRANCISCO. Datos registrales. T 46344 , F 71,
S 8, H M 813972, I/A 1 ( 1.02.24).
67759 - INSTALACIONES MINGORANCE SL.
Nombramientos. Apoderado: TRUEBA CHAO MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 46344 , F 72, S 8, H M 813972, I/A 2 (
1.02.24).
67760 - CEPSA SUSTAINABLE FUELS PUNTA DEL SEBO SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 12.01.24. Objeto social: Desarrollar, en España y en el extranjero, toda clase de actividades
industriales, comerciales, de servicios, corporativas o de promoción referidas, de modo principal, a materias primas, productos,
energías o sustancias relativas a la transición energética y la descarbonización de la industria y el. Domicilio: PASEO DE LA
CASTELLANA 259-A - TORRE CEPSA (MADRID). Capital: 10.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único:
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA. Nombramientos. Adm. Solid.: BERMEJO BECERRA VICTOR GERMAN;BARRASA
RUIZ CARLOS MIGUEL. Datos registrales. T 46303 , F 91, S 8, H M 813323, I/A 1 ( 1.02.24).
67761 - FMA CECOES SA.
Ceses/Dimisiones. Consejero: FRAISERO ARANGUREN GONZALO. Presidente: FRAISERO ARANGUREN GONZALO.
Cons.Del.Sol: FRAISERO ARANGUREN GONZALO. Nombramientos. Consejero: HEVIA OCHOA DE ECHAGUEN FRANCISCO.
Cons.Del.Sol: HEVIA OCHOA DE ECHAGUEN FRANCISCO. Presidente: MUNARRIZ BIGURIA JUAN JOSE. Reelecciones.
Consejero: ARANGUREN DIEZ ALFREDO. Secretario: ARANGUREN DIEZ ALFREDO. Consejero: MUNARRIZ BIGURIA JUAN JOSE.
Cons.Del.Sol: MUNARRIZ BIGURIA JUAN JOSE;ARANGUREN DIEZ ALFREDO. Datos registrales. T 29749 , F 154, S 8, H M
535260, I/A 5 ( 1.02.24).
67762 - OMEGA DELIVERY SL.
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30892 , F 126, S 8, H M 221365,
I/A 47 ( 1.02.24).

67764 - GRUPO LOFILMS ENTERTAINMENT SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 11.01.24. Objeto social: Construcción, Instalaciones y mantenimiento. Comercio al por
mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. Artes gráficas. Actividades inmobiliarias. Industrias
manufactureras y textiles. Turismo, hostelería y restauración. Agencia de viajes y organización, etc. Domicilio: AVDA CIUDAD DE
BARCELONA 222 - 4º-C (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: LOPEZ FERNANDEZ
ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 46275 , F 131, S 8, H M 812832,
I/A 1 ( 1.02.24).
67765 - PARQUE EOLICO VOLANDIN SL.
Nombramientos. Apoderado: MENENDEZ LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 41132 , F 30, S 8, H M 729300, I/A 15 ( 1.02.24).
67766 - PARQUE EOLICO VOLANDIN SL.
Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ MOURE MANUEL. Datos registrales. T 46204 , F 131, S 8, H M 729300, I/A 16 ( 1.02.24).

cve: BORME-A-2024-28-28
Verificable en https://www.boe.es

67763 - ALYON SERVICIOS SA.
Nombramientos. Apoderado: GALLARDO CASADO MARIA DEL PILAR;FERNANDEZ DE PINEDO PEREZ DE ARRILUCEA
BELTRAN. Datos registrales. T 43200 , F 202, S 8, H M 763322, I/A 17 ( 1.02.24).