SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2024-14-36)
PONTEVEDRA
6 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 14

Viernes 19 de enero de 2024

Pág. 3259

31196 - ATENCION SOCIAL Y RESIDENCIAL VALDEMORO SL.
Nombramientos. Apo.Sol.: SARRATO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4466, L 4466, F 76, S 8, H PO 64872,
I/A 55 (12.01.24).
31197 - SERVIGER XXI ALBACETE SL.
Nombramientos. Apo.Sol.: SARRATO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4461, L 4461, F 41, S 8, H PO 64689,
I/A 37 (12.01.24).
31198 - GERIAVI SA.
Nombramientos. Apo.Sol.: SARRATO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 26, S 8, H PO 59295,
I/A 65 (12.01.24).
31199 - ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS SL.
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3869, L 3869, F 198, S 8, H PO 54761, I/A 12 (12.01.24).
31200 - INFUSIONES Y TES DE GALICIA SL.
Otros conceptos: Establecimiento del carácter REMUNERADO del cargo de administrador y modificación del artículo 7º de los
estatutos sociales. Cambio de denominación social. PMS LOGISTIC SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA. Cambio de objeto
social. Actividad Principal: 47.91 / Comercio al por menor por correspondencia o Internet. Otras actividades: 46.19 / Intermediarios del
comercio de productos diversos; 47.78 / Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados; 47.19 /
Otro comercio al por menor en establecim. Datos registrales. T 4296, L 4296, F 205, S 8, H PO 65686, I/A 2 (12.01.24).
31201 - MANTERMIC SL.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: RODRIGUEZ GOMEZ JUAN. Adm. Unico: RODRIGUEZ GOMEZ JUAN. Revocaciones. Apo.Sol.:
RODRIGUEZ COSTAS ELISABET;RODRIGUEZ COSTAS JAVIER. Nombramientos. Liquidador: RODRIGUEZ GOMEZ JUAN.
Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 1616, L 1616, F 175, S 8, H PO 14383, I/A 7 (12.01.24).
31202 - PLAZA DE COMPOSTELA 17 SL.
Nombramientos. Apoderado: SALADO BARRANCO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4391, L 4391, F 129, S 8, H PO 69413,
I/A 4 (12.01.24).
31203 - INVERSIONES ANZUATEGUI SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BLANCO RODRIGUEZ PABLO;ALVAREZ GARCIA ISAAC. Nombramientos. Adm. Mancom.:
BLANCO RODRIGUEZ PABLO;FERNANDEZ GARCIA OSCAR. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración:
Administradores solidarios a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 4181, L 4181, F 217, S 8, H PO 61498, I/A 5
(12.01.24).
31204 - IBERICA DE CONGELADOS SA.
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4405, L 4405, F 222, S 8, H PO
5325, I/A 70 (12.01.24).
31205 - ADUANAS LOGISTICA TRANSPORTES E INTERMEDIACION EN UNIDADES DE SERVICIO SA.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: MARITIMA DAVILA SA. Datos registrales. T 4287, L 4287, F 177, S 8, H PO
27278, I/A 152 (12.01.24).
31206 - CENFER HLD SL.
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 3207, L 3207, F 53, S 8, H PO 40303, I/A 5 (12.01.24).

31208 - INVERSIONES LANTAÑON SOCIEDAD LIMITADA.
Constitución. Comienzo de operaciones: 14.12.23. Objeto social: CNAE 6420: Prestar todos los servicios de apoyo a la gestión que
las sociedades participadas requieran para la adecuada dirección y administración de su propio negocio, ya sea por medio del personal
de la Sociedad o de terceras personas. La adquisición y enajenación de acciones y participaciones. Domicilio: LUGAR LANTAÑON 41
(MEIS). Capital: 219.400,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: SABARIS ESCUDERO PABLO. Datos registrales. T 4472, L
4472, F 196, S 8, H PO 72640, I/A 1 (12.01.24).
31209 - INVERSIONES LANTAÑON SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: PEREZ ARGIBAY SARA. Datos registrales. T 4472, L 4472, F 198, S 8, H PO 72640, I/A 2 (12.01.24).

cve: BORME-A-2024-14-36
Verificable en https://www.boe.es

31207 - PRODUCTOS CONGELADOS SA.
Revocaciones. Auditor: CASTLE SPAIN AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: K4 IBERICA AUDITORES SOCIEDAD
LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 4269, L 4269, F 72, S 8, H PO 5849, I/A 45 (12.01.24).