SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2024-10-28)
MADRID
53 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 10

Lunes 15 de enero de 2024

Pág. 2188

mancomunados a Administradores solidarios. Cambio de domicilio social. C/ ARTURO SORIA 2 - PORTAL C, BAJO B (ALCALA
DE HENARES). Datos registrales. T 22891 , F 11, S 8, H M 409927, I/A 2 ( 8.01.24).
21037 - CRIMAYEL DESINFECCIONES TODAS LAS PLAGAS SL.
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GUTIERREZ HEVIA MARIA TERESA CRISTINA.
Nombramientos. Adm. Unico: SIERRA GUTIERREZ MANUEL. Ampliación de capital. Capital: 60.000,00 Euros. Resultante
Suscrito: 63.006,00 Euros. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. .
Cambio de domicilio social. JAZMIN 22 - BAJO DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 27025 , F 86, S 8, H M 486941, I/A 5 (
8.01.24).
21038 - OCEAN SEACRET SL.
Cambio de domicilio social. C/ MAHON 10 1ª C (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datos registrales. T 37934 , F 144, S 8, H M
675486, I/A 3 ( 8.01.24).
21039 - NOVABASE NEOTALENT ESPAÑA SA.
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA GONZALEZ MARCOS;CORONEL DE PALMA DE LA MATA ALFONSO ENRIQUE;ROVIRA
ESPADALER CARLA. Datos registrales. T 45522 , F 181, S 8, H M 305305, I/A 46 ( 8.01.24).
21040 - NOVABASE NEOTALENT ESPAÑA SA.
Ceses/Dimisiones. Consejero: FIGUEIREDO MORAIS ANTUNES FRANCISCO PAULO. Secretario: FIGUEIREDO MORAIS
ANTUNES FRANCISCO PAULO. Consejero: RODRIGUES VIEIRA CELIA-FERNANDA;DA SILVA FERREIRA ALVARO JOSE.
Presidente: DA SILVA FERREIRA ALVARO JOSE. Cons.Del.Sol: DA SILVA FERREIRA ALVARO JOSE. Cons.Del.Man: FIGUEIREDO
MORAIS ANTUNES FRANCISCO PAULO;RODRIGUES VIEIRA CELIA-FERNANDA. VsecrNoConsj: GARCIA ASTORGANO PEDRO.
Nombramientos. Adm. Unico: RODRIGUES VIEIRA CELIA-FERNANDA. Modificaciones estatutarias. Modificados los artículos 9 y
17 de los estatutos sociales.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador
único. Cambio de denominación social. CONCLUSION NEOTALENT ESPAÑA SA. Datos registrales. T 45522 , F 181, S 8, H M
305305, I/A 47 ( 8.01.24).
21041 - GLOBALTEAM CORPORATE SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 2.01.24. Objeto social: Actividad Principal : La compraventa e intermediación de toda clase
de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o
arrendamiento no financiero, y la construcción de toda clase de obras públicas o privadas... Domicilio: C/ JUAN BRAVO 3A BAJO
(MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA PASTRANA MARIA ELENA. Datos registrales. T
46213 , F 121, S 8, H M 811835, I/A 1 ( 8.01.24).
21042 - FCC MEDIO AMBIENTE SA.
Nombramientos. Apoderado: AGUAS MARTINEZ FELIPE CARMELO;ARNAIZ ARANO MARIA JOSEFA;ALVAREZ ALVAREZ
ISIDRO;GOMEZ MINGO JORGE LUIS;CARRASCO DELGADO JOSE MANUEL;DONOSO REBUELTA JOSE LUIS;ALDALUR
AIZPURU JOSE-JOAQUIN;PRIETO OTEO JUAN FELIX;ULIBARRI URRETXU AITOR. Datos registrales. T 45574 , F 221, S 8, H M
60671, I/A 1695 ( 8.01.24).
21043 - WESTERN UNION RETAIL SERVICES SPAIN SA.
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN GOMEZ GEMA. Datos registrales. T 28756 , F 33, S 8, H M 131092, I/A 297 ( 8.01.24).
21044 - GLOBAL STAY SL.
Reducción de capital. Importe reducción: 900.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.435.407,00 Euros. Datos registrales. T 40454 ,
F 93, S 8, H M 699137, I/A 12 ( 8.01.24).

21046 - VERSE LUX SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 23.11.23. Objeto social: a) Compra, venta, comercialización, distribución, importación y
exportación de maquinaria, vehículos automóviles e industriales, y sus accesorios, así como la preparación de los mismos. (CNAE
4511) ACTIVIDADES OMPLEMENTARIAS: b) Venta de otros vehículos de motor. (CNAE 4519) ..... Domicilio: C/ FISICAS 30 POLIGONO INDUSTRIAL URTINSA (ALCORCON). Capital: 3.050,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: GOMEZ MAROTO
JOSE-LUIS;VERGARA CASTRO SERGIO;DE LA RIVA MARTINEZ MARIO. Datos registrales. T 46176 , F 100, S 8, H M 811191, I/A
1 ( 8.01.24).
21047 - SOUTH CAPRI CORPORATE SL.
Revocaciones. Apoderado: AGUILAR VICO ANTONIO;MONTAÑEZ SANCHEZ DANIEL;CHAPA DIAZ JORGE. Datos registrales. T
43185 , F 27, S 8, H M 763110, I/A 6 ( 8.01.24).

cve: BORME-A-2024-10-28
Verificable en https://www.boe.es

21045 - ORBIGO POR MALASAÑA SL.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: GURDIEL ROBLES CARLOS. Adm. Solid.: GURDIEL ROBLES CARLOS;ALONSO FUERTES
SHEILA. Nombramientos. Liquidador: GURDIEL ROBLES CARLOS. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T
39589 , F 22, S 8, H M 702690, I/A 2 ( 8.01.24).