SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2024-10-08)
BARCELONA
43 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 10

Lunes 15 de enero de 2024

Pág. 2106

20043 - SPEED GAS MOTOR SL.
Revocaciones. ADM.UNICO: MORATONA COLOM ANDRES. LIQUIDADOR: MORATONA COLOM ANDRES. Nombramientos.
LIQUIDADOR: MORATONA COLOM ANDRES. Extinción. Datos registrales. T 45465 , F 158, S 8, H B 488750, I/A 6 ( 5.01.24).
20044 - LA GENT DE LLETRES SL.
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: CORTES GARRETA JUAN;TERRATS MIRALLES MARCOS. LIQUIDADOR: TERRATS MIRALLES
MARCOS. Nombramientos. LIQUIDADOR: TERRATS MIRALLES MARCOS. Extinción. Datos registrales. T 36682 , F 155, S 8,
H B 282666, I/A 3 ( 5.01.24).
20045 - GESTORIA DOCUGEST SL.
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: LOPEZ VILLA SONIA;CRISENTI MALAGON LUIS EMILIO. LIQUIDADOR: CRISENTI MALAGON
LUIS EMILIO;LOPEZ VILLA SONIA. Nombramientos. LIQUIDADOR: CRISENTI MALAGON LUIS EMILIO;LOPEZ VILLA SONIA.
Extinción. Datos registrales. T 39418 , F 105, S 8, H B 344828, I/A 8 ( 5.01.24).
20046 - SPAGOUR SL.
Revocaciones. ADM.UNICO: GALVEZ ARCOS AYRTON JOHN. LIQUIDADOR: GALVEZ ARCOS AYRTON JOHN.
Nombramientos. LIQUIDADOR: GALVEZ ARCOS AYRTON JOHN. Extinción. Datos registrales. T 44905 , F 161, S 8, H B
470944, I/A 3 ( 5.01.24).
20047 - DELECTA TECHNOLOGIES SL.
Reducción de capital. Importe reducción: 10.370,00 Euros. Resultante Suscrito: 53.064,00 Euros. Datos registrales. T 44959 , F
225, S 8, H B 457173, I/A 8 ( 5.01.24).
20048 - SEVEN&MILA EVENTS SL.
Ampliación de capital. Capital: 20.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.060,00 Euros. Datos registrales. T 44430 , F 196, S 8, H B
455843, I/A 5 ( 5.01.24).
20049 - LA FURGONETA ANOIA S.L.
Ampliación de capital. Capital: 113.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 116.000,00 Euros. Cambio de domicilio social. CL
CERVANTES NUM. 18, H 2 (IGUALADA). Datos registrales. T 48107 , F 29, S 8, H B 572551, I/A 2 ( 4.01.24).
20050 - CODING GIANTS S.L.
Ampliación de capital. Capital: 1.170,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.500,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ADICION
ART.10 BIS Y ART.15 BIS: ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION POR
MEDIOS TELEMATICOS. Datos registrales. T 47181 , F 65, S 8, H B 543850, I/A 5 ( 4.01.24).
20051 - SURREALISMO INVERSIONES S.L.
Ampliación de capital. Capital: 2.700.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.703.000,00 Euros. Datos registrales. T 47002 , F 21, S
8, H B 537818, I/A 3 ( 5.01.24).
20052 - FRALLOR RESIDENTIAL S.L.
Ampliación de capital. Capital: 150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros. Cambio de domicilio social. CL
MUNTANER Num.262 P.1 PTA.4 (BARCELONA). Datos registrales. T 48835 , F 89, S 8, H B 598011, I/A 3 ( 4.01.24).

20054 - ESTRAPERLO SL.
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: PERET POZO DAVID;SABATES AMETLLER JORDI. LIQUIDADOR: PERET POZO DAVID.
Nombramientos. LIQUIDADOR: PERET POZO DAVID. Extinción. Datos registrales. T 40970 , F 21, S 8, H B 374340, I/A 4 (
5.01.24).
20055 - LAMDA STAR SL.
Ampliación de capital. Capital: 225.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 228.608,00 Euros. Datos registrales. T 33664 , F 92, S 8, H
B 233542, I/A 5 ( 5.01.24).
20056 - GESTAMP ABRERA SA.
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: GESTAMP SOLBLANK NAVARRA SL. Datos registrales. T 47856 , F 74, S 8, H B
156627, I/A 80 ( 5.01.24).

cve: BORME-A-2024-10-08
Verificable en https://www.boe.es

20053 - ROSA D'ABRIL SL.
Reducción de capital. Importe reducción: 20.016,00 Euros. Resultante Suscrito: 78.510,00 Euros. Datos registrales. T 35723 , F
131, S 8, H B 277736, I/A 7 ( 5.01.24).