SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2024-6-28)
MADRID
80 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 6

Martes 9 de enero de 2024

Pág. 1237

11857 - RUIZ-JARABO ASOCIADOS SL.
Extinción. Datos registrales. T 20749 , F 176, S 8, H M 367563, I/A 5 ( 2.01.24).
11858 - CHAMARTIN MADRID 2017 SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PUGA FERNANDEZ MANUEL-MARIA. Revocaciones. Apoderado: GARCIA GIMENO
CARLOS;MARTINEZ FERNANDEZ VERONICA;RUIZ GARCIA CARLOS HUGO. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales.
T 36219 , F 126, S 8, H M 650850, I/A 8 ( 2.01.24).
11859 - GLOBAL EURO PARTNERS SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ OLIVEROS NIEVES. Nombramientos. Consejero: LLORENTE FERNANDEZ
FERNANDO. Presidente: LLORENTE FERNANDEZ FERNANDO. Con.Delegado: LLORENTE FERNANDEZ FERNANDO. Consejero:
LLORENTE FERNANDEZ CESAR. Secretario: LLORENTE FERNANDEZ CESAR. Consejero: LLORENTE MARTIN MARIANO. Otros
conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T 31682 , F
64, S 8, H M 570085, I/A 3 ( 2.01.24).
11860 - DON PLANET MADRID SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PUGA FERNANDEZ MANUEL-MARIA. Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA GIMENO
CARLOS;MARTINEZ FERNANDEZ VERONICA;RUIZ GARCIA CARLOS HUGO. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales.
T 35153 , F 56, S 8, H M 632181, I/A 6 ( 2.01.24).
11861 - FAMILY OFFICE SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPOS GUALLAR ISABEL. Datos registrales. T 26430 , F 221, S 8, H M 476309, I/A 13 ( 2.01.24).
11862 - FAMILY OFFICE SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apo.Sol.: BRINGAS DE LA LASTRA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 26430 , F 222, S 8, H M 476309, I/A 14
( 2.01.24).
11863 - SOMEREBI SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BUENO HERNANDEZ CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: SANTOS NEYRA FERNANDO
JOSE. Cambio de domicilio social. C/ RAMON POWER 42 - 2º C (MADRID). Datos registrales. T 24614 , F 155, S 8, H M
443049, I/A 7 ( 2.01.24).
11864 - SOMEREBI SL.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: SANTOS NEYRA FERNANDO JOSE. Datos registrales. T 24614 , F 155, S 8, H M
443049, I/A 8 ( 2.01.24).
11865 - INFANTE 1980 SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PUGA FERNANDEZ MANUEL-MARIA. Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA GIMENO
CARLOS;MARTINEZ FERNANDEZ VERONICA;RUIZ GARCIA CARLOS HUGO. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales.
T 36458 , F 134, S 8, H M 655032, I/A 6 ( 2.01.24).
11866 - MAD T1 CAR 2017 SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PUGA FERNANDEZ MANUEL-MARIA. Revocaciones. Apoderado: GARCIA GIMENO
CARLOS;MARTINEZ FERNANDEZ VERONICA;RUIZ GARCIA CARLOS HUGO. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales.
T 36230 , F 158, S 8, H M 651032, I/A 6 ( 2.01.24).

11868 - VEMARE SL.
Reelecciones. Auditor: ALMAGRO AUDITORES SL. Datos registrales. T 36912 , F 128, S 8, H M 73843, I/A 59 ( 2.01.24).
11869 - MAPUFE VTC SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PUGA FERNANDEZ MANUEL-MARIA. Revocaciones. Apoderado: GARCIA GIMENO
CARLOS;MARTINEZ MARTINEZ VERONICA;RUIZ GARCIA CARLOS HUGO. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T
36226 , F 223, S 8, H M 650968, I/A 8 ( 2.01.24).
11870 - IFSES EDUCACION SL.
Ampliacion del objeto social. - Actividades sanitarias entre las que se incluyen tratamiento de medicina, nutrición, belleza y estética.
-La explotación, administración, gestión y franquicia de clínicas médico-estéticas. - La realización de tratamientos de estética,
ortodoncia, lipoescultura, celulitis y en general todas las ... Datos registrales. T 38194 , F 179, S 8, H M 679649, I/A 20 ( 2.01.24).

cve: BORME-A-2024-6-28
Verificable en https://www.boe.es

11867 - CLOUDWARE SL.
Ampliación de capital. Capital: 617,00 Euros. Resultante Suscrito: 41.649,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los
estatutos: Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales. Datos registrales. T 40295 , F 103, S 8, H M 654453, I/A 15 (
2.01.24).