SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2024-1-28)
MADRID
58 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 1

Martes 2 de enero de 2024

Pág. 105

1418 - IXAS VALUE SL.
Ceses/Dimisiones. Consejero: VALLEJO SUAREZ DE PUGA GUILLERMO;LUNA GOMEZ JESUS;HENRIQUEZ DE LUNA
BASAGOITI FRANCISCO DE BORJA. Presidente: VALLEJO SUAREZ DE PUGA GUILLERMO. Secretario: HENRIQUEZ DE LUNA
BASAGOITI FRANCISCO DE BORJA. Revocaciones. Apo.Man.Soli: LUNA GOMEZ JESUS;VALLEJO SUAREZ DE PUGA
GUILLERMO;HENRIQUEZ DE LUNA BASAGOITI FRANCISCO DE BORJA. Nombramientos. Liquidador: LUNA GOMEZ JESUS.
Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 38177 , F 178, S 8, H M 679347, I/A 5 (22.12.23).
1419 - PARAMAÑANA SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 28.11.23. Objeto social: Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos
especializados. Publicidad y merchandising. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total
o parciamente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedad.. Domicilio: C/ RONDA DE LA
FUENTE 9 - LOCAL (PARACUELLOS DE JARAMA). Capital: 100,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: MUÑOZ MORENO
ANTONIO. Datos registrales. T 46172 , F 1, S 8, H M 811114, I/A 1 (23.12.23).
1420 - MONTAJE OCHENTA Y OCHO SL EN LIQUIDACION.
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MUÑOZ REPISO CARREÑO MARIA DEL CARMEN;ZARATE MUÑOZ REPISO JUAN CARLOS.
Nombramientos. LiquiSoli: GOMEZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER. Liquidador: DE CARLOS BERTRAN JOSE MANUEL.
Disolución. Voluntaria. Datos registrales. T 12946 , F 224, S 8, H M 7222, I/A 14 (22.12.23).
1421 - SONER VELAZQUEZ SOCIEDAD LIMITADA.
Constitución. Comienzo de operaciones: 23.11.23. Objeto social: (1) La realización de toda clase de actividades, obras y servicios
propios o relacionados con los negocios de: a) Promoción, desarrollo, construcción, operación, mantenimiento y gestión de proyectos y
de instalaciones de almacenamiento de energía y de generación de energía eléctrica de origen... Domicilio: PASEO DE LA
CASTELLANA 81 - PLANTA 15 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: SUNGROW
RENEWABLE ENERGY SPAIN SL. Nombramientos. Adm. Unico: SANCHEZ RUIZ DANIEL. Datos registrales. T 46132 , F 210, S
8, H M 810506, I/A 1 (22.12.23).
1422 - SONER VELAZQUEZ SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: LI SHI. Datos registrales. T 46132 , F 211, S 8, H M 810506, I/A 2 (22.12.23).
1423 - REPSOL DIRECTO SA.
Revocaciones. Apo.Sol.: CABRERO ACOSTA JAVIER;ESPAÑOL LORENTE ELENA;GALAN CALDERON MARIA DEL
ROCIO;LEDANOIS CASTAÑEDA ELODIE FLORENCE. Datos registrales. T 39817 , F 153, S 8, H M 203054, I/A 259 (22.12.23).
1424 - SUNNY PROPERTIES SPAIN SL.
Modificaciones estatutarias. Modificado el artículo 33º de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 25403 , F 147, S 8, H M
457575, I/A 2 (22.12.23).
1425 - GLOBAL ADAPA SL.
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 25. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 32480 , F 16, S 8, H M
584635, I/A 12 (22.12.23).
1426 - ZONA CERO EMISIONES SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALCAZAR LEBRATO MANUEL. Nombramientos. Liquidador: ALCAZAR LEBRATO MANUEL.
Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 40032 , F 207, S 8, H M 711252, I/A 3 (22.12.23).

1428 - AZORA CORPORATE SERVICES SL.
Ceses/Dimisiones. Representan: RODRIGUEZ HEREDIA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: GONZALEZ DIEZ
MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 43019 , F 216, S 8, H M 581074, I/A 10 (22.12.23).
1429 - EURO COLVEN SA.
Cambio de domicilio social. C/ GONZALO CHACON 62 (ARANJUEZ). Datos registrales. T 46107 , F 183, S 8, H M 810109, I/A 2
(22.12.23).
1430 - POPULOUS DESIGN AND CONSULTANCY SL.
Nombramientos. Apoderado: WALKER CHRISTOPHER;BAXENDINE ANDREW;RICHARDS STUART PETER;SHARKEY DECLAN
JOSEPH;ABBEY ELIZABETH;SHARKEY DECLAN JOSEPH. Datos registrales. T 45936 , F 173, S 8, H M 807270, I/A 3 (22.12.23).

cve: BORME-A-2024-1-28
Verificable en https://www.boe.es

1427 - MORA DISEÑOS SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 26.12.23. Objeto social: Comercio al por menor por correspondencia o Internet. Domicilio:
CALLE SAN DACIO Número33 1 IZ (MADRID). Capital: 400,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: TAMAYO
MORA MELIZA. Nombramientos. Adm. Unico: TAMAYO MORA MELIZA. Datos registrales. T 46155 , F 40, S 8, H M 810865, I/A 1
(22.12.23).