SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2023-64-28)
MADRID
54 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 64

Lunes 3 de abril de 2023

Pág. 16877

(27.03.23).
160235 - SOLUTIONS 30 IBERIA 2017 SL.
Ceses/Dimisiones. Consejero: FORTIS RUGGERO. Presidente: FORTIS RUGGERO. Con.Delegado: FORTIS RUGGERO.
Nombramientos. Consejero: FANDIÑO PEÑALVER JUAN ROMAN. Presidente: FANDIÑO PEÑALVER JUAN ROMAN. Datos
registrales. T 40340 , F 104, S 8, H M 96238, I/A 44 (27.03.23).
160236 - FILIAL DE TENEDORA DOS SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 17.03.23. Objeto social: a) Promoción inmobiliaria. b) Construcción de toda clase de
edificaciones. c) Compra y venta de toda clase de bienes inmuebles, así como su intervención. d) Otras actividades de consultoría de
gestión empresarial. Domicilio: C/ DE BRASIL 29 - 1ª PLANTA (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico:
TENEDORA DE PARTICIPACIONES Y GESTORA DE NEGOCIOS. Representan: ANTON GARRIGA JUAN JOSE. Datos
registrales. T 44887 , F 180, S 8, H M 790275, I/A 1 (27.03.23).
160237 - PIÑATA ARANJUEZ SL.
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GUTIERREZ RUIZ CRISTINA. Datos registrales. T 32411 , F 159, S
8, H M 583387, I/A 5 (27.03.23).
160238 - PIÑATA ARANJUEZ SL.
Nombramientos. Apoderado: NUCSOREANU CATALINA STEFANIA. Datos registrales. T 32411 , F 160, S 8, H M 583387, I/A 6
(27.03.23).
160239 - TRANSPORTES KB 1979 SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 27.03.23. Objeto social: Transporte de mercancías por carretera. Domicilio: C/ SAN
LAMBERTO 21 3 B (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: NEILA RODRIGUEZ
MARIO. Nombramientos. Adm. Unico: NEILA RODRIGUEZ MARIO. Datos registrales. T 44940 , F 80, S 8, H M 791163, I/A 1
(27.03.23).
160240 - PROSEGUR CASH SA.
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 42681 , F 53, S 8, H M 619528, I/A 125 (27.03.23).
160241 - PROSEGUR CASH SA.
Nombramientos. Apoderado: SANZ LOSADA JOSE MARIA. Datos registrales. T 42681 , F 53, S 8, H M 619528, I/A 126 (27.03.23).
160242 - DECORACIONES AIJIA SL.
Nombramientos. Apoderado: LIN MEILING. Datos registrales. T 44919 , F 1, S 8, H M 790751, I/A 2 (27.03.23).
160243 - INVERSIONES CIT 2 SL.
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 41466 , F 12, S 8, H M 605697, I/A 52 (27.03.23).
160244 - INVERSIONES CIT 2 SL.
Nombramientos. Apoderado: SANZ LOSADA JOSE MARIA. Datos registrales. T 41466 , F 12, S 8, H M 605697, I/A 53 (27.03.23).

160246 - MADRID VERTICAL TVD SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 1.03.23. Objeto social: Reformas de construcción y rehabilitación (trabajos de altura,
trabajos de albañilería, de fontanería, de electricidad, de pintura, reformas en general). La explotación de establecimientos de
peluquerías, institutos de belleza y gabinetes de estética y el franquiciado de las mismas. Domicilio: C/ RAYO 5 4º - LETRA G
(GETAFE). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: MARTIN MANZANO CARLOS.
Nombramientos. Adm. Unico: MARTIN MANZANO CARLOS. Datos registrales. T 44911 , F 150, S 8, H M 790618, I/A 1 (27.03.23).
160247 - CHEETAH MARKETING TECHNOLOGY SPAIN SL.
Nombramientos. Apoderado: GANDOY FERNANDEZ ISABEL;ORIACH I ROQUETA XAVIER;SANZ PEREZ MARCO
ANTONIO;SIGNES ESPUCH JULIA. Datos registrales. T 36195 , F 113, S 8, H M 650461, I/A 12 (27.03.23).
160248 - CHEETAH MARKETING TECHNOLOGY SPAIN SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RAZZINO WILLIAM ROBERT;MOSBY BRENT DAVIS. Nombramientos. Adm. Unico: DILLARD III
JOHN WELLFORD. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único.
Datos registrales. T 36195 , F 114, S 8, H M 650461, I/A 13 (27.03.23).

cve: BORME-A-2023-64-28
Verificable en https://www.boe.es

160245 - NETWORK STEEL RESOURCES SA.
Cambio de domicilio social. C/ CARDENAL HERRERA ORIA 383 (MADRID). Datos registrales. T 41874 , F 104, S 8, H M 424429,
I/A 28 (27.03.23).