SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2023-57-28)
MADRID
65 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 57

Jueves 23 de marzo de 2023

Pág. 14912

141965 - COMERCIAL AGRICOLA ARAGONESA SA.
Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ QUESADA JUAN. Datos registrales. T 2553 , F 216, S 8, H M 44537, I/A 15 (15.03.23).
141966 - ENZYME IBERIA SL.
Revocaciones. Apoderado: ORTIN BARBERAN ALVARO. Datos registrales. T 36866 , F 28, S 8, H M 659732, I/A 6 (15.03.23).
141967 - KAROL JPK CARTERA SICAV SA.
Ceses/Dimisiones. Consejero: PERQUY GERARD LOUIS. Secretario: PERQUY GERARD LOUIS. Consejero: CLAPES COLOMAR
MARC;COLOMAR COLOMAR CAROLINA. Presidente: COLOMAR COLOMAR CAROLINA. VsecrNoConsj: ROJO RIVERA MARIA
ELENA. Ent. Gestora: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SOCIEDAD ANONIMA. EntidDeposit: CACEIS BANK SPAIN SA.
Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Nombramientos. Liquidador: COLOMAR
COLOMAR CAROLINA. Liq.Sup.: PERQUY GERARD LOUIS. Datos registrales. T 24942 , F 83, S 8, H M 449117, I/A 29 (15.03.23).
141968 - DUNAS VALOR EQUILIBRIO FONDO DE PENSIONES.
Modificaciones estatutarias. Modificados los artículos 1º y 5º. Cambio de denominación social. DUNAS VALOR EQUILIBRADO
FONDO DE PENSIONES. Datos registrales. T 36394 , F 3, S 8, H M 653872, I/A 7 (15.03.23).
141969 - LEX & LU MANAGEMENT SL.
Ampliación de capital. Capital: 29.870,00 Euros. Resultante Suscrito: 32.870,00 Euros. Datos registrales. T 40479 , F 84, S 8, H M
718688, I/A 3 (15.03.23).
141970 - MECANISMOS AUTOMATICOS INDUSTRIALES SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: SEDANO RODRIGUEZ DE LA FLOR CRISTINA. Datos registrales. T 3310 , F 42, S 8, H M 56189, I/A
8 (15.03.23).
141971 - TALKDESK SPAIN SL.
Nombramientos. Apoderado: WILBUR SHAUNA GERAGHTY. Datos registrales. T 44425 , F 84, S 8, H M 782860, I/A 4 (15.03.23).
141972 - MH BOXING SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 3.03.23. Objeto social: a) Gimnasio deportivo. b) Comercio menor y mayor de material
deportivo, incluyendo ropa e instrumentos relacionados con el deporte y el boxeo. c) Comercio menor y mayor de alimentos para
deportistas y bebidas ,isotónicas, proteicas, hidratantes para el deporte. d) Celebración, organización... Domicilio: C/ SANTIBAÑEZ DE
BEJAR 1 - PLANTA BAJA, LOCAL 2 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: HERNANDEZ GARCIA
SUSANA;GONZALEZ MATIAS ANTONIO. Datos registrales. T 44885 , F 150, S 8, H M 790230, I/A 1 (15.03.23).
141973 - TOUCHPOINT SL.
Modificaciones estatutarias. 1. Modificación de la redacción de los artículos 1º y 3º de los estatutos sociales.- . Datos registrales. T
43545 , F 93, S 8, H M 768935, I/A 3 (15.03.23).

141975 - MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA.
Revocaciones. Apoderado: SANZ NAVARRETE JUAN JOSE;SANZ NAVARRETE JUAN JOSE;CABALLERO GOMEZ JOSE
MARIA;SANCHEZ CABANES ANTONIO. Apo.Man.Soli: GUARCH BONORA VICENTE;OLAGUE ALBERRO MIGUEL;GUARCH
BONORA VICENTE. Apoderado: GIL LUNA LUIS MIGUEL;ARJONA ROMERO JUAN ANTONIO;MARCO ORENES FRANCISCO
JOSE;OLAGUE ALBERO MIGUEL JOSE;BRAÑA HERNANDEZ JUAN EVANGELISTA;TEIXIDO MUNTALT JOAQUIN;CABALLERO
GOMEZ JOSE MARIA;MARCO ORENES FRANCISCO JOSE;HORTAL TURMO JAVIER;GIL LUNA LUIS MIGUEL. Apo.Man.Soli:
CABALLERO GOMEZ JOSE MARIA;SANCHEZ CABANES ANTONIO. Apoderado: RAMOS MANZANARO JUAN JOSE;RAMOS
MANZANARO JUAN JOSE. Apo.Sol.: ZALACAIN LINACISORO JON MARTIN. Datos registrales. T 34740 , F 112, S 8, H M 9333, I/A
635 (15.03.23).
141976 - ACP FACTORY SL.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: GARCIA MARIN CHRISTIAN DAVID. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTIZ
TORO LADY JOHANA. Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA MARIN CHRISTIAN DAVID. Modificaciones estatutarias. Artículo
de los estatutos: 3. Domicilio social . Cambio de domicilio social. C/ JULIA NEBOT 14 - BAJO C (MADRID). Datos registrales. T
30988 , F 2, S 8, H M 557756, I/A 2 (15.03.23).
141977 - JOMASA ALQUILER DE MAQUINARIA SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 7.03.23. Objeto social: La compra, venta, importación y exportación de materiales de
construcción, electricidad, fontanería, carpintería y maquinaria, para obras y construcción así como alquiler o arrendamiento de
maquinaria. - El transporte por carretera de toda clase de mercancías, bultos y paquetería. - El estudio, dis. Domicilio: C/ LA GRANJA 7

cve: BORME-A-2023-57-28
Verificable en https://www.boe.es

141974 - CORNERSTONE ONDEMAND SPAIN SL.
Nombramientos. Apoderado: COURSON RYAN CAMERON. Apo.Sol.: WAGNER AMANDA JERUSHA;WARD AARON;BECK
ZACKARY;KIDD DAVID;SIMS CHERYL;GARDNER MICHAEL. Datos registrales. T 37621 , F 197, S 8, H M 670404, I/A 9 (15.03.23).