SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2022-233-28)
MADRID
51 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 233

Viernes 9 de diciembre de 2022

Pág. 56589

T 36947 , F 40, S 8, H M 272888, I/A 36 (30.11.22).
538465 - VALDEMERA AGROPECUARIA SL.
Nombramientos. Presidente: DINARAMICO SL. Datos registrales. T 36947 , F 40, S 8, H M 272888, I/A 37 (30.11.22).
538466 - TRACOR SA EN LIQUIDACION.
Situación concursal. Procedimiento concursal 87/2022. FIRME: No, Fecha de resolución 18/11/2022. Auto de aprobación del plan de
liquidación. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 15 DE MADRID. Juez: TEODORO LADRON RODA.
Situación concursal. Procedimiento concursal 87/2022. FIRME: No, Fecha de resolución 18/11/2022. Auto de formación de la
sección de calificación. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 15 DE MADRID. Juez: TEODORO LADRON
RODA. Resoluciones: Formación de la sección sexta de calificación del concurso. Datos registrales. T 19654 , F 208, S 8, H M
67469, I/A B (30.11.22).
538467 - MUNTANIA OUTDOORS SL.
Nombramientos. Apoderado: DE SIMON FERMOSELL NURIA. Datos registrales. T 29158 , F 191, S 8, H M 524988, I/A 5
(30.11.22).
538468 - DISTRIBUCIONES CAFIN SA.
Situación concursal. Procedimiento concursal 229/2022. FIRME: Si, Fecha de resolución 6/09/2022. Auto de declaración de
concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID. Juez: OLGA AHEDO PEÑA.
Resoluciones: Declarada la sociedad en concurso voluntario. Situación concursal. Procedimiento concursal 229/2022. FIRME: Si,
Fecha de resolución 6/09/2022. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO
MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID. Juez: OLGA AHEDO PEÑA. Resoluciones: Conclusión del procedimiento concursal, por
insuficiencia de masa activa. Extinción de la sociedad y cierre de su hoja de inscripción. Extinción. Datos registrales. T 12203 , F
52, S 8, H M 193008, I/A 11 (30.11.22).
538469 - ARDIAN SPAIN SL.
Revocaciones. Apo.Manc.: ANGOITIA GRIJALBA JUAN;FERNANDEZ ALBIÑANA GONZALO. Apo.Sol.: VILLATTE EP LAVAILLOT
AUDREY MARIE LILIA. Apoderado: FERNANDEZ ALBIÑANA GONZALO;FERNANDEZ ALBIÑANA GONZALO. Nombramientos.
Cons.Ejecuti: EGGINS EDMUND CHARLES;SANZ CARRASQUEÑO ALVARO. Apoderado: FERNANDEZ ALBIÑANA
GONZALO;EGGINS EDMUND CHARLES;SANZ CARRASQUEÑO ALVARO. Datos registrales. T 38860 , F 121, S 8, H M 595126,
I/A 14 (30.11.22).
538470 - CUCS DESIGN SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MAYERANOFF LLADO MARIA DE LOS REYES. Nombramientos. Adm. Solid.: DRAKE RUIZMORALES CARMEN. Cambio de domicilio social. C/ PIO XII 8 4º (MADRID). Datos registrales. T 41418 , F 179, S 8, H M
734012, I/A 2 (30.11.22).

538472 - ENERGYHUNTERS SLL.
Ampliación de capital. Capital: 30.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 96.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Modificados
los artículos 6 y 11 de los estatutos sociales.. Ampliacion del objeto social. INVESTIGACION, REDACCION Y EDICION DE
ARTICULOS, O TEXTOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PARA PUBLICACIONES VARIAS EN CUALQUIER FORMATO, INCLUIDO
GUIONADO Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES. PRODUCCION Y VENTA, FISICA O DIGITAL, DE LIBROS Y PUBLICACIONES,
O CUALQUIER OTRO MATERIAL GRAFICO O AUDIOVISUAL. Datos registrales. T 37683 , F 165, S 8, H M 671395, I/A 5
(30.11.22).
538473 - MARPANI SOLAR 9 SL.
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES SL. Datos registrales. T 43922 , F 1, S 8, H M 677529, I/A 14 (30.11.22).
538474 - HOSPITAL MAJADAHONDA SA.
Ampliación de capital. Suscrito: 107.700,00 Euros. Desembolsado: 107.700,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.709.500,00 Euros.
Resultante Desembolsado: 19.709.500,00 Euros. Datos registrales. T 40710 , F 39, S 8, H M 376917, I/A 84 (30.11.22).

cve: BORME-A-2022-233-28
Verificable en https://www.boe.es

538471 - COLEGIO ALCALA SL.
Ceses/Dimisiones. Consejero: FREAN CALDAS PEDRO JUAN;PEREZ MONDELO MARIA DEL CARMEN;FREAN PEREZ MARIA
DEL PILAR;FREAN PEREZ PEDRO;FREAN PEREZ JOSE MANUEL. Presidente: FREAN CALDAS PEDRO JUAN. Secretario: PEREZ
MONDELO MARIA DEL CARMEN. Cons.Del.Sol: FREAN CALDAS PEDRO JUAN;PEREZ MONDELO MARIA DEL CARMEN.
Nombramientos. Apoderado: FREAN PEREZ PEDRO. Consejero: FREAN PEREZ PEDRO;FREAN PEREZ JOSE MANUEL.
Presidente: FREAN PEREZ JOSE MANUEL. Cons.Del.Man: FREAN PEREZ PEDRO;FREAN PEREZ JOSE MANUEL. Consejero:
FREAN PEREZ MARIA DEL PILAR. Secretario: FREAN PEREZ MARIA DEL PILAR. Cons.Del.Man: FREAN PEREZ MARIA DEL
PILAR. Datos registrales. T 5134 , F 16, S 8, H M 84073, I/A 5 (30.11.22).