SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2022-231-28)
MADRID
59 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 231

Lunes 5 de diciembre de 2022

Pág. 56083

MANUEL. Datos registrales. T 17108 , F 224, S 8, H M 292978, I/A 29 (28.11.22).
533573 - ACCENTURE SL.
Revocaciones. Apoderado: GARRIDO-ARROQUIA NOVES JOAQUINA;ABAD GOMEZ ANA BELEN;GALLEGO RODRIGUEZ
CARLOS -ENRIQUE. Apo.Sol.: FERRERAS ELETA ANGEL;GALLEGO RODRIGUEZ CARLOS -ENRIQUE. Apoderado: GARRIDOARROQUIA NOVES JOAQUINA. Apo.Sol.: FERNANDEZ RIVERO LAURA. Datos registrales. T 42889 , F 68, S 8, H M 18421, I/A
380 (28.11.22).
533574 - ACCENTURE SL.
Nombramientos. Apoderado: COSTALES CASANOVA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 42889 , F 68, S 8, H M 18421, I/A 381
(28.11.22).
533575 - ACCENTURE SL.
Nombramientos. Apoderado: PEREZ PRADA BERNABE;PERALTA LOZANO PABLO. Datos registrales. T 42889 , F 69, S 8, H M
18421, I/A 382 (28.11.22).
533576 - ALBERIZA ENERGIA SOLAR SL.
Cambio de domicilio social. C/ SALIENTE 128 (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 44243 , F 87, S 8, H M 780020, I/A
2 (28.11.22).
533577 - PICO ESQUINA PROPERTIES SL.
Nombramientos. Apoderado: BLANCO ARNALDO RAMON. Datos registrales. T 39743 , F 214, S 8, H M 706167, I/A 3 (28.11.22).
533578 - PICO ESQUINA PROPERTIES SL.
Cambio de domicilio social. C/ CASTILLO DE FUENSALDAÑA 4, 217 (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datos registrales. T 39743 , F
215, S 8, H M 706167, I/A 4 (28.11.22).
533579 - SANTANDER CONSUMER FINANCE SA.
Nombramientos. Apo.Manc.: SALAZAR JUAREZ TOMAS VICENTE;ALGUACIL PRIETO IGNACIO;VACAS REBOLLO
JORGE;ESCOBEDO MAGALDI CARMEN. Datos registrales. T 38662 , F 180, S 8, H M 7029, I/A 2183 (28.11.22).
533580 - FAST ITALIA SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SABAN GARCIA LEONARDO. Nombramientos. Liquidador: SABAN GARCIA LEONARDO.
Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 32235 , F 48, S 8, H M 580185, I/A 3 (28.11.22).
533581 - SERVICIOS DE HOSTELERIA ARMANDO FERREIRA SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERREIRA CASTELO ARMANDO. Nombramientos. Liquidador: FERREIRA CASTELO
ARMANDO. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 29337 , F 83, S 8, H M 528072, I/A 2 (28.11.22).
533582 - FESOR SPV 2021 SL.
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 42060 , F 164, S 8, H M 744734,
I/A 5 (28.11.22).
533583 - G T G SERVICIOS DIVERSOS SL.
Ampliación de capital. Capital: 3.006,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.012,00 Euros. Cambio de domicilio social. C/
ANOCHECER, 2, OFICINA 3 (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 29032 , F 182, S 8, H M 143821, I/A 14 (28.11.22).

533585 - INTEGRANDO FD SL.
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ampliación de capital. Capital: 499.168,00 Euros. Resultante Suscrito: 507.668,00
Euros. Ampliación de capital. Capital: 332,00 Euros. Resultante Suscrito: 508.000,00 Euros. Datos registrales. T 39435 , F 60, S
8, H M 700125, I/A 4 (28.11.22).
533586 - TEAMTOP PROJECTS SL.
Nombramientos. Apoderado: MAZOYER PATRICE PAUL MARIE. Datos registrales. T 36914 , F 133, S 8, H M 660296, I/A 18
(28.11.22).

cve: BORME-A-2022-231-28
Verificable en https://www.boe.es

533584 - FABREGA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA.
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARRETERO FABREGA JAIME. Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 10 de los
Estatutos Sociales: Sistema de retribución del órgano de administración. . Página web de la sociedad. Creación de la página web
corporativa: www.fabregaconstructora.com. Datos registrales. T 40251 , F 218, S 8, H M 26402, I/A 117 (28.11.22).