SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2022-227-28)
MADRID
57 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 227

Martes 29 de noviembre de 2022

Pág. 55061

523926 - AGUAS DE LAS GALERAS SL.
Revocaciones. Apoderado: PARRA MEDIAVILLA FELIX. Nombramientos. Apo.Sol.: PARRA MEDIAVILLA FELIX. Datos
registrales. T 40651 , F 9, S 8, H M 580752, I/A 35 (22.11.22).
523927 - VERALIA CORPORACION DE PRODUCTORAS DE CINE Y TELEVISION SOCIEDAD LIMITADA.
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32338 , F 216, S 8, H M 491163,
I/A 38 (22.11.22).
523928 - HOSTELERIA CONJUNTA SL.
Modificaciones estatutarias. Modificación del articulo 29º de los Estatutos Sociales . Datos registrales. T 21111 , F 177, S 8, H M
374803, I/A 9 (22.11.22).
523929 - NORMAVISION SL.
Otros conceptos: Se subsana el error padecido al indicar en la escritura de otorgamiento de poder con numero de protocolo 5122/22
el DNI de don Javier Martos Garcia siendo el correcto 07480556J. Datos registrales. T 4933 , F 48, S 8, H M 80687, I/A 8 (22.11.22).
523930 - ALQUIBER QUALITY SA.
Nombramientos. Apoderado: FRAILE GARCIA VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 30044 , F 207, S 8, H M 540720, I/A 32
(22.11.22).
523931 - VERTEX ESPAÑA SL.
Nombramientos. Apo.Sol.: FERREIRA SOTO MANUEL. Datos registrales. T 1446 , F 95, S 8, H M 26867, I/A 3 (22.11.22).
523932 - PUNTO DE FUGA INVESTIGACION PROSPECTIVA SL.
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: WALIÑO DAVILA SEBASTIAN. Datos registrales. T 31778 , F 63, S 8, H M 571821, I/A 7
(22.11.22).
523933 - TORRE RA SOCIEDAD LIMITADA.
Constitución. Comienzo de operaciones: 23.09.22. Objeto social: EXPLOTACION AGRICOLA DE FINCAS DE CULTIVO INTENSIVO
DE OLIVOS. Domicilio: C/ MESENA 22 (MADRID). Capital: 150.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único:
SORIA VAQUERIZO ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: SORIA VAQUERIZO ANGEL. Datos registrales. T 43984 , F 178, S 8,
H M 775923, I/A 1 ( 5.10.22).
523934 - PROCOM DESARROLLOS URBANOS SA.
Reducción de capital. Importe reducción: 253.980,00 Euros. Resultante Suscrito: 106.020,00 Euros. Datos registrales. T 23186 , F
97, S 8, H M 314490, I/A 49 (22.11.22).
523935 - CASTILLO ARABE - MARRAKECH SL.
Nombramientos. Apoderado: ACHIBAN KAMAL. Datos registrales. T 43925 , F 202, S 8, H M 775068, I/A 2 (22.11.22).
523936 - BUGUROO TECHNOLOGIES RESEARCH SOFTWARE SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE LA RIVA FERREZUELO PABLO. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ FERREZUELO
SANDRA. Apoderado: DE LA RIVA FERREZUELO PABLO. Cambio de domicilio social. C/ ERAS DE CARRABELVIS 27
(COBEÑA). Datos registrales. T 28265 , F 182, S 8, H M 509100, I/A 2 (22.11.22).

523938 - EXPERIS MANPOWERGROUP SL.
Nombramientos. Apoderado: BLAZQUEZ BENITO MYRIAM;DA CUNHA LOMBA DIAS RIBEIRO FRANCISCO JOAO;CAPARROS
JIMENEZ JAVIER;VILA CABRE JORDI. Datos registrales. T 36005 , F 90, S 8, H M 226917, I/A 82 (22.11.22).
523939 - EXPERIS MANPOWERGROUP SL.
Revocaciones. Apoderado: EXPOSITO FUSTER FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 36005 , F 91, S 8, H M 226917, I/A 83
(22.11.22).
523940 - BUSINESS ONE COFFEE IMPORT SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DIAZ FREY VICTOR MANUEL. Nombramientos. Liquidador: DIAZ FREY VICTOR MANUEL.
Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 41151 , F 142, S 8, H M 729602, I/A 3 (22.11.22).

cve: BORME-A-2022-227-28
Verificable en https://www.boe.es

523937 - SEINE CONSULTORES SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE LA TORRE GARRIDO ERNESTO. Nombramientos. Adm. Unico: DE LA TORRE HERRANZ
RICARDO. Datos registrales. T 13605 , F 66, S 8, H M 221450, I/A 7 (22.11.22).