SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos. (BORME-A-2021-99-28)
MADRID
46 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99

Jueves 27 de mayo de 2021

Pág. 26672

255605 - DESERT EXTREME SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ESMORIS LLORCA ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: KAPITALIA INVERSION 2019 SL.
Representan: GARCIA LINARES FONTES FEDERICO. Cambio de domicilio social. C/ MAURICIO LEGENDRE 6 4 A (MADRID).
Cambio de objeto social. ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION EMPRESARIAL, LA INTERMEDIACION EN EL
ASESORAMIENTO DE EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS EN SU MAS AMPLIA ACEPCION EN LOS AMBITOS COMERCIAL,
LABORAL, TECNICO... Datos registrales. T 41702 , F 57, S 8, H M 738697, I/A 2 (20.05.21).
255606 - CARBURANTES GPLOIL SL.
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MONTAVEZ DANIEL. Datos registrales. T 41457 , F 167, S 8, H M 734649, I/A 2 (20.05.21).
255607 - TAKE A K2K SL.
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CABIQUETA ARRAZOLA GALDER. Nombramientos.
Consejero: CABIQUETA ARRAZOLA GALDER. Presidente: CABIQUETA ARRAZOLA GALDER. Consejero: LOPEZ MORENO
RUBEN. Secretario: LOPEZ MORENO RUBEN. Consejero: BRAÑAS BAZTAN PABLO. Ampliación de capital. Capital: 20.816,00
Euros. Resultante Suscrito: 40.816,00 Euros. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a
Consejo de administración. Se modifican los Articulos 7º, 10º y 18º de los Estatutos. Cambio de domicilio social. C/ CALCARLOS
36 - 3B (MADRID). Datos registrales. T 29846 , F 91, S 8, H M 537014, I/A 6 (20.05.21).
255608 - TAKE A K2K SL.
Nombramientos. Con.Delegado: CABIQUETA ARRAZOLA GALDER. Datos registrales. T 41785 , F 90, S 8, H M 537014, I/A 7
(20.05.21).
255609 - ALODIA-FARMACEUTICA SL.
Ampliacion del objeto social. La investigación, desarrollo, producción y comercialización de toda clase de moléculas, principios y
productos bioactivos con aplicación particular, pero no exclusiva, en el campo de la cosmética, la medicina humana y animal. La
Formulación productos insecticidas, fungicidas, herbicidas..... Datos registrales. T 35605 , F 74, S 8, H M 639924, I/A 6 (20.05.21).
255610 - JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL.
Nombramientos. Apoderado: CRUZ-VILLALON GARCIA DIEGO;GONZALEZ OJEDA MARIA ISABEL;MORENO GOMEZ IGNACIO
JAVIER;RICHARD HAWRYSCH ENRIQUE;VARELA CORREA LAURA. Datos registrales. T 36311 , F 48, S 8, H M 46201, I/A 106
(20.05.21).
255611 - CENTRO MEDICO COSTA RICA SL.
Ceses/Dimisiones. Presidente: TINTO DEL VAL JOSE ANTONIO. Secretario: TRILLO GONZALEZ JUAN CARLOS. Consejero:
TRILLO GONZALEZ JUAN CARLOS;MUÑOZ GUTIERREZ JUAN;TINTO DEL VAL JOSE ANTONIO. Cons.Del.Sol: TRILLO
GONZALEZ JUAN CARLOS;TINTO DEL VAL JOSE ANTONIO. Nombramientos. Liquidador: TINTO DEL VAL JOSE ANTONIO.
Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 5973 , F 30, S 8, H M 97690, I/A 4 (20.05.21).
255612 - GRUPO SEG PRESTACION DE SERVICIOS SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 3.11.20. Objeto social: La realización de todo tipo de proyectos, memoria e informes,
asistencia técnica y estudios de carácter téenicos, económico, sociológico, urbanísticos, civiles, industriales, comerciales y
administrativos, en los campos de edificación, civil, aeroportuaria, aeroespacial, industrial, forestal, etc... Domicilio: C/ SERRANO 43-45
- 4ª PLANTA, PUERTA 7 (MADRID). Capital: 103.275,84 Euros. Nombramientos. Consejero: D ALESSANDRO GUSTAVO;GARCIACORDERO CELIS ANGEL;GARCIA-CORDERO CELIS GERMAN LUIS;FERNANDEZ LARREA SOCORRO;FERNANDEZ GOMEZ
JAIME ANTONIO;RODRIGUEZ GRACIA JUAN GERARDO;SERRANO VALDIVIESO JUAN CARLOS. Presidente: GARCIACORDERO CELIS ANGEL. Vicepresid.: FERNANDEZ GOMEZ JAIME ANTONIO. Con.Delegado: GARCIA-CORDERO CELIS
GERMAN LUIS. VsecrNoConsj: LLAVERO PEREDA DANIEL JESUS. SecreNoConsj: VIVANCOS GASSET FLORENTINO. Datos
registrales. T 41782 , F 79, S 8, H M 740118, I/A 1 (20.05.21).

255614 - SASABE INVERSIONES SICAV SA.
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BUGALLO ADAN MONICA. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZ PEREIRA EVA.
Datos registrales. T 29340 , F 76, S 8, H M 528139, I/A 11 (20.05.21).
255615 - MAIEUSTEN SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 10.05.21. Objeto social: LA ADQUISICION, ADMINISTRACION Y ENAJENACION, Y EN
GENERAL TENENCIA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE OTRAS
SOCIEDADES... Domicilio: C/ HERMOSILLA 7 - 2º - 9 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio
único: BELMAIN CORPORATE SL. Nombramientos. Adm. Unico: MONROY GIMENO SERGIO-FRANCISCO. Datos registrales. T
41936 , F 70, S 8, H M 742615, I/A 1 (20.05.21).

cve: BORME-A-2021-99-28
Verificable en https://www.boe.es

255613 - NUEVA DIMENSION NOVA-MADRID SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTIN SUÑE MANUEL ANTONIO. Datos registrales. T 34831 , F 104, S 8, H M 626462, I/A 2
(20.05.21).